Entreprises

Entreprise : recherchez, téléchargez vos documents, enrichissez et suivez vos sociétés clés en un clic.

Video de présentation : Entreprises

Listes personnalisées : Créez des listes sur mesure, en illimité… et toujours gratuites

Prospection sur-mesure : Enrichissez vos listes ou résultats de recherches avec téléphones, e-mails et autres

Exportation des données : Exportez facilement le contenus de vos listes ou résultats de recherches

Alertes & plus : Recevez en temps réel des notifications personnalisées sur chaque évolution

Annonces MAPA
11 459
Annonces d’autres sources
387 422
Annonces du JOUE
75 991
Annonces du BOAMP
168 198
Retour

SOMADIS SOC MAGDUNOISE DISTRIBUTIONFermé

Branche d'activité principale

Supermarchés

Code APE/NAF

47.11D
Copy

Date de création

20/06/2002

Date de clôture

28/01/2025

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Adresse du SIRET

RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59170 CROIX

SIREN

442726923
Copy

SIRET Principal

44272692300042
Copy

Nr. TVA

FR36442726923
Copy

Capital

3 M €

Chiffre d'affaire 2020

982 k €

Effectif

NN

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300018
Copy

Adresse du SIRET

51 RTE D ORLEANS 45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Date de création

20/06/2002

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300034
Copy

Adresse du SIRET

RUE DE LA RABATERIE 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Date de création

11/05/2005

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300026
Copy

Adresse du SIRET

4 RUE DES MOULINS 51700 DORMANS

Date de création

01/06/2005

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300059
Copy

Adresse du SIRET

LIEU DIT LES HARCHES RTE DE LAON 02800 CHARMES

Date de création

01/03/2006

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300067
Copy

Adresse du SIRET

89 RUE JOSEPH BERTRAND 78220 VIROFLAY

Date de création

01/01/2008

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300075
Copy

Adresse du SIRET

RTE DE VEIGNE 37320 ESVRES

Date de création

19/03/2008

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300083
Copy

Adresse du SIRET

49 RUE DEVILDE 37000 TOURS

Date de création

05/06/2008

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300091
Copy

Adresse du SIRET

8 A 10 8 AV D OCEANIE 91940 LES ULIS

Date de création

11/01/2010

Etablissement secondaire

Fermé

SIRET

44272692300109
Copy

Adresse du SIRET

134 RUE PASCAL 92160 ANTONY

Date de création

01/01/2016

Siège

Fermé

SIRET

44272692300042
Copy

Adresse du SIRET

RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 59170 CROIX

Date de création

01/09/2005

Les données des bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation gouvernementale depuis le 31/07/2024. Contactez-nous pour en savoir plus

Historique de la société

Pas de données sur les employés de cette société

12/08/2021

CA_442726923_5910_2006B20579_2020_19414

Télécharger

12/02/2021

CA_442726923_5910_2006B20579_2019_3441

Télécharger

19/08/2019

CA_442726923_5910_2006B20579_2018_16550

Télécharger

26/10/2018

CA_442726923_5910_2006B20579_2017_18553

Télécharger

16/10/2017

CA_442726923_5910_2006B20579_2016_16881

Télécharger

16/10/2017

CA_442726923_5910_2006B20579_2016_16881.pdf

Télécharger

26/10/2018

CA_442726923_5910_2006B20579_2017_18553.pdf

Télécharger

19/08/2019

CA_442726923_5910_2006B20579_2018_16550.pdf

Télécharger

22/02/2021

CA_442726923_5910_2006B20579_2019_3441.pdf

Télécharger

04/09/2021

CA_442726923_5910_2006B20579_2020_19414.pdf

Télécharger

25/06/2021

7qh9raPCT4yt_C0022A1001L222930D20210630H184418TPIJTES003PDBOR

Télécharger

06/10/2017

zYDlhBXunusb_C0022A1001L351775D20171027H171915TPIJTES003PDBOR

Télécharger

27/08/2015

55313342000000_C0022A1001L375790D20150914H172445TPIJTES003PDBOR

Télécharger

12/07/2013

26470036000000_C0022A1001L046894D20150218H212019TPIJTES003PDBOR

Télécharger

19/01/2012

LCdkEkQ2wmxa_RACT2_442726923_5910_2006B20579_2012_320045001

Télécharger

28/05/2010

NRPscXpsLqD4_RACT2_442726923_5910_2006B20579_2010_300276401

Télécharger

Abonnez-vous à notre service Marchés Publics pour accéder à ces données
Voir les tarifs

Abonnez-vous à notre service Marchés Publics pour accéder à ces données
Voir les tarifs

04/11/2021 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Radiations

29/08/2021 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

29/06/2021 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Ventes et cessions

29/06/2021 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Ventes et cessions

29/06/2021 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Ventes et cessions

02/03/2021 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

11/09/2019 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

23/11/2018 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

17/11/2017 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

14/09/2016 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

13/09/2015 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

Modifications diverses

31/08/2015 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

29/09/2014 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

31/08/2013 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

Dépôts des comptes

30/07/2013 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

Modifications diverses

10/12/2012 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Dépôts des comptes

22/05/2012 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS

Ventes et cessions

29/01/2012 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Modifications diverses

25/10/2011 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Dépôts des comptes

13/09/2011 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Dépôts des comptes

11/06/2010 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Modifications diverses

16/03/2010 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

Modifications diverses

21/12/2009 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Dépôts des comptes

17/02/2009 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Modifications diverses

29/09/2008 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Dépôts des comptes

18/03/2008 - GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING

Modifications diverses

03/02/2009

dNAXRgHN85Nz_RACT0900291674

Télécharger

22/08/2008

OyJdCF7QlFKj_RACT0800165233

Télécharger

05/03/2008

UR77IIOK05gL_RACT0800016465

Télécharger

12/03/2007

gORD7u4BWoY5_RACT0700320055

Télécharger

26/04/2006

79fxqDHfmwIZ_RACT0600996303

Télécharger

03/05/2004

qu6R3NliKTIq_RACT0400712213

Télécharger

15/07/2002

Rzbxyv9xJPgJ_RACT0200214365

Télécharger

Abonnez-vous à notre service Immobilier pour accéder à ces données
Voir les tarifs

Pas de marques déposées pour cette société